-
ST PANCRAS WAY PROPCO LIMITED - Ashcroft House Ervington Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08749412
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ashcroft House Ervington Court
- Meridian Business Park
- Leicester
- LE19 1WL Ashcroft House Ervington Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL UK
Management
- Geschäftsführung
- CAMERON, Peter Stuart
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.10.2013
- Alter der Firma 2013-10-25 10 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- BIG LOBSTER LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 2138005WW499QWO6EC25
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-10-31
- Letzte Einreichung: 2020-01-25
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-06
- Letzte Einreichung: 2019-10-25
-
ST PANCRAS WAY PROPCO LIMITED Firmenbeschreibung
- ST PANCRAS WAY PROPCO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08749412. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.10.2013 registriert. ST PANCRAS WAY PROPCO LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BIG LOBSTER LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Ashcroft House Ervington Court erreicht werden.
Jetzt sichern ST PANCRAS WAY PROPCO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: St Pancras Way Propco Limited - Ashcroft House Ervington Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL, Grossbritannien
- 2013-10-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ST PANCRAS WAY PROPCO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-10-26) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
auditors-resignation-company (2020-09-29) - AUD
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-07-03) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-03) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-07-03) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-07-03) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-03) - MR04
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-01-07) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-07-03) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-07-03) - PSC08
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-30) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2020-07-29) - CERTNM
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-08-13) - SH02
-
capital-allotment-shares (2020-08-14) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-09-21) - AA
-
resolution (2020-09-24) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-09-24) - 600
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2020-09-24) - LIQ01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-01) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-09-30) - MR01
-
resolution (2019-10-14) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-01) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-04-01) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-11-05) - AA
-
memorandum-articles (2019-11-21) - MA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-03) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-10) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-12-19) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-06) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-11-13) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-11-03) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-11-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-03) - CS01
-
memorandum-articles (2016-01-29) - MA
-
resolution (2016-01-29) - RESOLUTIONS
-
resolution (2016-01-18) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-05) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-18) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-11) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-11-11) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-11-11) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-06-24) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-10-25) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-12-24) - AA01