-
DIMENSIONS SOMERSET SEV LIMITED - 1430 Arlington Business Park, Theale, Reading, RG7 4SA, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10257343
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1430 Arlington Business Park, Theale
- Reading
- RG7 4SA
- England 1430 Arlington Business Park, Theale, Reading, RG7 4SA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FLETCHER, Jacqueline Linda
- HAIGH, Alastair James
- LLOYD-EVANS, Delyth Anne
- MCLAUGHLAN, Stephen Michael
- MCNAB, Angela
- STRONG, Steve Martin
- TAVARE, Harry
- CHEETHAM, Stella Margaret
- CARSON, Christine Anne
- ENGLAND, Neil
- Prokuristen
- GREENBANK, Joanne Marie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-limited-guarant-nsc
- Gründungsdatum
- 29.06.2016
- Alter der Firma 2016-06-29 8 Jahre
- SIC/NACE
- 87200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dimensions (Uk) Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-12
- Letzte Einreichung: 2020-06-28
-
DIMENSIONS SOMERSET SEV LIMITED Firmenbeschreibung
- DIMENSIONS SOMERSET SEV LIMITED ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc registrierte Firma mit der Register-Nr. 10257343. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 29.06.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87200" registriert. Das Unternehmen hat 10 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1430 Arlington Business Park, Theale erreicht werden.
Jetzt sichern DIMENSIONS SOMERSET SEV LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dimensions Somerset Sev Limited - 1430 Arlington Business Park, Theale, Reading, RG7 4SA, England, Grossbritannien
- 2016-06-29
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DIMENSIONS SOMERSET SEV LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-31) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-01-11) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-02-09) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-16) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-10-13) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-09-23) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-09-23) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-29) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-21) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-22) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-10-23) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-12-05) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-14) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-11) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-12-12) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-29) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-02) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-20) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-03-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-19) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-10-10) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-28) - PSC02
-
statement-of-companys-objects (2017-04-11) - CC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-08) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-19) - AP01
-
resolution (2017-03-21) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-04-10) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-12) - TM01
-
resolution (2017-04-11) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-07-13) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-07-13) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-08) - TM01
-
incorporation-company (2016-06-29) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-21) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-07-27) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-13) - TM01