-
J PILLING FENCING CONTRACTORS LTD - 61, Stanley Road, Bootle, Merseyside, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04477520
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 61
- Stanley Road
- Bootle
- Merseyside
- L20 7BZ 61, Stanley Road, Bootle, Merseyside, L20 7BZ UK
Management
- Geschäftsführung
- PILLING, John Derek
- PILLING, Leslie Robert
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.07.2002
- Gelöscht am:
- 2020-09-22
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Leslie Robert Pilling
- Mr John Derek Pilling
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-12-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-07-04
-
J PILLING FENCING CONTRACTORS LTD Firmenbeschreibung
- J PILLING FENCING CONTRACTORS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04477520. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 04.07.2002 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 04.07.2012.Die Firma kann schriftlich über 61 erreicht werden.
Jetzt sichern J PILLING FENCING CONTRACTORS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: J Pilling Fencing Contractors Ltd - 61, Stanley Road, Bootle, Merseyside, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu J PILLING FENCING CONTRACTORS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-09-22) - GAZ2(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-01-16) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2020-01-28) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-20) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-22) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-14) - CS01
-
elect-to-keep-the-directors-register-information-on-the-public-register (2016-07-14) - EH01
-
elect-to-keep-the-secretaries-register-information-on-the-public-register (2016-07-14) - EH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-15) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-10) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-24) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-07-04) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-25) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-04-10) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-10) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-01-10) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-11-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-12) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-12) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-07-12) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-04) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-13) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-07) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-03-06) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-09) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-01-08) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-11) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-04-25) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-07-19) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-04-12) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-03-21) - AA
-
legacy (2005-07-04) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-04-01) - AA
-
legacy (2004-07-13) - 363s
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-07-12) - 363s
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-07-27) - 88(2)R
-
legacy (2002-07-27) - 225
-
legacy (2002-07-27) - 287
-
legacy (2002-07-27) - 288a
-
legacy (2002-07-10) - 288b
-
incorporation-company (2002-07-04) - NEWINC