-
RENEWABLE SERVICES LIMITED - 507 St Pancras Chambers, Euston Road, London, NW1 2AR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 04479470
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 507 St Pancras Chambers
- Euston Road
- London
- NW1 2AR
- England 507 St Pancras Chambers, Euston Road, London, NW1 2AR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CALCRAFT, William Joseph
- Prokuristen
- CALCRAFT, Una Imelda
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.07.2002
- Gelöscht am:
- 2020-10-06
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Una Imelda Calcraft
- Mr William Joseph Calcraft
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2018-07-31
-
RENEWABLE SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- RENEWABLE SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 04479470. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 08.07.2002 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.07.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 507 St Pancras Chambers erreicht werden.
Jetzt sichern RENEWABLE SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Renewable Services Limited - 507 St Pancras Chambers, Euston Road, London, NW1 2AR, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu RENEWABLE SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-10-06) - GAZ2(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-04-19) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2020-04-28) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-08) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-08) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-18) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-05) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-09) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-07-09) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-05) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-07-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-22) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-08-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-31) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-10-14) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-05-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-23) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-06-02) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-28) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-07-08) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-07-23) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-06-06) - AA
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-07-27) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-05-16) - AA
keyboard_arrow_right 2005
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2005-04-29) - AA
-
legacy (2005-11-11) - 363s
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-07-19) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2004-05-21) - AA
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-07-28) - 363s
keyboard_arrow_right 2002
-
legacy (2002-10-08) - 287
-
legacy (2002-10-08) - 288a
-
legacy (2002-07-18) - 287
-
legacy (2002-07-18) - 288b
-
incorporation-company (2002-07-08) - NEWINC