-
THAMES VALLEY REFURBISHMENT LIMITED - 5 Minton Place, Victoria Road, Bicester, Oxon, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05382268
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 Minton Place
- Victoria Road
- Bicester
- Oxon
- OX26 6QB 5 Minton Place, Victoria Road, Bicester, Oxon, OX26 6QB UK
Management
- Geschäftsführung
- KENDALL, Nicholas Paul
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.03.2005
- Alter der Firma 2005-03-03 19 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nicholas Paul Kendall
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-03-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-17
- Letzte Einreichung: 2023-03-03
-
THAMES VALLEY REFURBISHMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- THAMES VALLEY REFURBISHMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05382268. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.03.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.03.2013.Die Firma kann schriftlich über 5 Minton Place erreicht werden.
Jetzt sichern THAMES VALLEY REFURBISHMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Thames Valley Refurbishment Limited - 5 Minton Place, Victoria Road, Bicester, Oxon, Grossbritannien
- 2005-03-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THAMES VALLEY REFURBISHMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-11-17) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-03-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-05) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-11) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-04-10) - TM02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-10) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-20) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-06) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-03-21) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2012-03-21) - CH03
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-07) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-03) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-04) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-01-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-12-22) - AA
-
legacy (2009-03-04) - 288c
-
legacy (2009-03-04) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-11-14) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-10-10) - AA
-
legacy (2008-03-07) - 363a
-
legacy (2008-03-07) - 288c
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-03-23) - 288c
-
legacy (2007-03-23) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-08-21) - AA
-
legacy (2007-04-13) - 288c
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-06-27) - 287
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2006-06-23) - AA
-
legacy (2006-06-07) - 288b
-
legacy (2006-03-30) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-03-16) - 287
-
incorporation-company (2005-03-03) - NEWINC
-
legacy (2005-04-05) - 288b
-
legacy (2005-04-04) - 288b
-
legacy (2005-03-16) - 288a