-
BRASSINGTON CHARTERING LTD - The White House, Mill Road, Goring On Thames, RG8 9DD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05409629
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The White House
- Mill Road
- Goring On Thames
- RG8 9DD The White House, Mill Road, Goring On Thames, RG8 9DD UK
Management
- Geschäftsführung
- HEATHCOTE, Peter Johnathan Antoine
- Prokuristen
- MORTIMER BURNETT LTD
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 31.03.2005
- Alter der Firma 2005-03-31 19 Jahre
- SIC/NACE
- 50200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Peter Johnathan Antoine Heathcote
- Peter Johnathan Antoine Heathcote
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-12
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
-
BRASSINGTON CHARTERING LTD Firmenbeschreibung
- BRASSINGTON CHARTERING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05409629. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 31.03.2005 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "50200" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.03.2012.Die Firma kann schriftlich über The White House erreicht werden.
Jetzt sichern BRASSINGTON CHARTERING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Brassington Chartering Ltd - The White House, Mill Road, Goring On Thames, RG8 9DD, Grossbritannien
- 2005-03-31
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRASSINGTON CHARTERING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-05-04) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-05-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-01-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-09-26) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-09-26) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-04) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-31) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-03) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-22) - AR01
-
move-registers-to-registered-office-company (2014-05-22) - AD04
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-31) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-25) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-04-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-06-21) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-06-21) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-10) - AR01
-
change-sail-address-company-with-old-address (2012-04-10) - AD02
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-13) - AA
-
capital-allotment-shares (2011-04-13) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-01-05) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-20) - CH01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-04-20) - CH04
-
change-sail-address-company (2010-04-20) - AD02
-
move-registers-to-sail-company (2010-04-20) - AD03
-
capital-allotment-shares (2010-04-20) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2010-12-14) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-11-23) - AA
-
legacy (2009-04-02) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-12-10) - AA
-
legacy (2008-04-03) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2007-07-03) - AA
-
legacy (2007-04-04) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-04-25) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2006-09-06) - AA
-
legacy (2006-04-25) - 288a
-
legacy (2006-04-25) - 363a
keyboard_arrow_right 2005
-
incorporation-company (2005-03-31) - NEWINC