-
VIR2 LTD. - 11 Glendale, Swanmore, Southampton, SO32 2QY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05464025
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 11 Glendale
- Swanmore
- Southampton
- SO32 2QY
- England 11 Glendale, Swanmore, Southampton, SO32 2QY, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CRAVEN, Roger David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.05.2005
- Alter der Firma 2005-05-26 19 Jahre
- SIC/NACE
- 62030
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Roger David Craven
- Mrs Gine Louise Houghton Craven
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- GIVITAGO LTD.
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-02-28
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-09
- Letzte Einreichung: 2020-05-26
-
VIR2 LTD. Firmenbeschreibung
- VIR2 LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05464025. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.05.2005 registriert. VIR2 LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GIVITAGO LTD. ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62030" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/05/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 11 Glendale erreicht werden.
Jetzt sichern VIR2 LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vir2 Ltd. - 11 Glendale, Swanmore, Southampton, SO32 2QY, Grossbritannien
- 2005-05-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VIR2 LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-02-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-03-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-05-25) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-03) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-03) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-24) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-22) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-23) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-07-22) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-21) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-21) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-02) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-28) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-03-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-02-03) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-08-13) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-02-25) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-14) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-02-11) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-01) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-06-07) - 353
-
legacy (2007-06-07) - 288c
-
legacy (2007-06-08) - 288c
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2007-03-26) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2007-10-18) - CERTNM
-
memorandum-articles (2007-10-24) - MEM/ARTS
-
legacy (2007-06-08) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
memorandum-articles (2006-10-12) - MEM/ARTS
-
certificate-change-of-name-company (2006-10-10) - CERTNM
-
legacy (2006-09-05) - 287
-
legacy (2006-06-14) - 363s
keyboard_arrow_right 2005
-
resolution (2005-08-19) - RESOLUTIONS
-
legacy (2005-08-19) - 88(2)R
-
legacy (2005-08-19) - 288b
-
legacy (2005-08-19) - 288a
-
certificate-change-of-name-company (2005-07-29) - CERTNM
-
incorporation-company (2005-05-26) - NEWINC