-
NEW WORLD PLANT DECOR LTD - 9 Sycamore Road, Birstall, Leicester, LE4 4LW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05810772
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9 Sycamore Road
- Birstall
- Leicester
- LE4 4LW
- England 9 Sycamore Road, Birstall, Leicester, LE4 4LW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- JACOBS, Scott
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.05.2006
- Alter der Firma 2006-05-09 18 Jahre
- SIC/NACE
- 81300
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Rose Jacobs
- Mr Scott Jacobs
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-01-31
- Letzte Einreichung: 2020-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-26
- Letzte Einreichung: 2021-05-12
-
NEW WORLD PLANT DECOR LTD Firmenbeschreibung
- NEW WORLD PLANT DECOR LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05810772. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.05.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "81300" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.05.2012.Die Firma kann schriftlich über 9 Sycamore Road erreicht werden.
Jetzt sichern NEW WORLD PLANT DECOR LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: New World Plant Decor Ltd - 9 Sycamore Road, Birstall, Leicester, LE4 4LW, Grossbritannien
- 2006-05-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEW WORLD PLANT DECOR LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-02) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-04-20) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-04-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-15) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2020-10-07) - CH03
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-10-07) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-10-07) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-07) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-06) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-12) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-04-29) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-28) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2020-03-31) - GAZ1
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-10-07) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-17) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-15) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-01-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-05-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-06-24) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-06-24) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-02-27) - AA
-
legacy (2009-05-20) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-01-30) - AA
-
legacy (2008-07-03) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-05-21) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-05-18) - 225
-
legacy (2006-05-18) - 288c
-
incorporation-company (2006-05-09) - NEWINC