-
BRENVALE LIMITED - Chilton Airfield, Waldingfield Road, Sudbury, Suffolk, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 05852570
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Chilton Airfield
- Waldingfield Road
- Sudbury
- Suffolk
- CO10 0RB Chilton Airfield, Waldingfield Road, Sudbury, Suffolk, CO10 0RB UK
Management
- Geschäftsführung
- MAY, David Frederick
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.06.2006
- Alter der Firma 2006-06-20 18 Jahre
- SIC/NACE
- 77120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Lord May Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-04
- Letzte Einreichung: 2021-06-20
-
BRENVALE LIMITED Firmenbeschreibung
- BRENVALE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 05852570. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.06.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77120" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.06.2012.Die Firma kann schriftlich über Chilton Airfield erreicht werden.
Jetzt sichern BRENVALE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Brenvale Limited - Chilton Airfield, Waldingfield Road, Sudbury, Suffolk, Grossbritannien
- 2006-06-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRENVALE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-12) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-03-24) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-03-24) - PSC02
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-12-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-19) - TM02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-22) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-19) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-10-19) - PSC04
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-12-14) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-10-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-27) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2012-10-24) - DISS40
-
gazette-notice-compulsary (2012-10-23) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
legacy (2011-12-14) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-05) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-19) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-07-14) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-14) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-07-14) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-03-18) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-11-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-08-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-09-07) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-29) - 288a
-
legacy (2008-10-29) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-09-01) - AA
-
legacy (2008-08-20) - 363s
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2008-05-14) - AA
-
legacy (2008-02-14) - 225
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-09-25) - 363s
-
legacy (2007-05-02) - 288a
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-06-20) - NEWINC
-
legacy (2006-08-29) - 287
-
legacy (2006-10-18) - 395