-
DUNHAM GREYHOUND CENTRE LTD - Cabourn House, Station Street, Bingham, Nottinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06040675
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Cabourn House
- Station Street
- Bingham
- Nottinghamshire
- NG13 8AQ
- England Cabourn House, Station Street, Bingham, Nottinghamshire, NG13 8AQ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HOUFTON, David Lewis
- HOUFTON, Jayne Alison
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.01.2007
- Alter der Firma 2007-01-03 17 Jahre
- SIC/NACE
- 93199
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Jane Alison Houfton
- Mr David Lewis Houfton
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- LOOK ALIVE RACING LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-03
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-14
- Letzte Einreichung: 2020-01-03
-
DUNHAM GREYHOUND CENTRE LTD Firmenbeschreibung
- DUNHAM GREYHOUND CENTRE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06040675. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.01.2007 registriert. DUNHAM GREYHOUND CENTRE LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen LOOK ALIVE RACING LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93199" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 03.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Cabourn House erreicht werden.
Jetzt sichern DUNHAM GREYHOUND CENTRE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dunham Greyhound Centre Ltd - Cabourn House, Station Street, Bingham, Nottinghamshire, Grossbritannien
- 2007-01-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DUNHAM GREYHOUND CENTRE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-08-26) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-05-29) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-15) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-19) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-19) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-01-19) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
certificate-change-of-name-company (2016-10-14) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2016-10-14) - CONNOT
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-24) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-secretary-company-with-name (2013-09-24) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-11-12) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-10-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-01-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-01-25) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2010-09-01) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2010-12-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-12-29) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-08) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-05-28) - 288b
-
legacy (2009-05-28) - 288a
-
legacy (2009-01-08) - 363a
keyboard_arrow_right 2008
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-10-24) - AA
-
legacy (2008-01-07) - 363a
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-12-22) - 225
-
incorporation-company (2007-01-03) - NEWINC