-
DUAL CONTROL LTD - 14 Clifton Moor Business Village, James Nicolson Link, York, YO30 4XG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06385770
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 14 Clifton Moor Business Village
- James Nicolson Link
- York
- YO30 4XG
- England 14 Clifton Moor Business Village, James Nicolson Link, York, YO30 4XG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ORMISTON, Robert Wallace
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.10.2007
- Gelöscht am:
- 2023-06-13
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Kevin Gamble
- Mrs Joanne Lyon
- -
- -
- Northern Tonic Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-15
- Letzte Einreichung: 2022-10-01
-
DUAL CONTROL LTD Firmenbeschreibung
- DUAL CONTROL LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06385770. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 01.10.2007 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 14 Clifton Moor Business Village erreicht werden.
Jetzt sichern DUAL CONTROL LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dual Control Ltd - 14 Clifton Moor Business Village, James Nicolson Link, York, YO30 4XG, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DUAL CONTROL LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-03-17) - DS01
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-02-07) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-02-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-02-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-02-07) - TM02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-02-07) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-02-07) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2022-04-13) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-29) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-02) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-11) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-07) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-10) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-07) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-24) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-19) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-05-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-04-11) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-04-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-10-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2009-10-27) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2009-10-27) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-05-14) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-10-17) - 363a
-
legacy (2008-10-16) - 288c
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-10-02) - 288b
-
legacy (2007-11-20) - 225
-
legacy (2007-10-17) - 88(2)R
-
legacy (2007-10-17) - 288a
-
incorporation-company (2007-10-01) - NEWINC