-
BRIDGE COURT (FARNHAM) LIMITED - Newtown House, 38 Newtown Road, Liphook, Hampshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06517015
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Newtown House
- 38 Newtown Road
- Liphook
- Hampshire
- GU30 7DX Newtown House, 38 Newtown Road, Liphook, Hampshire, GU30 7DX UK
Management
- Geschäftsführung
- BLUNT, Dominic Malcolm, Dr
- DAVIES, Christopher William David
- TURNER, Tony
- YOUNG, Neil Martin
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.02.2008
- Alter der Firma 2008-02-28 16 Jahre
- SIC/NACE
- 68320
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-08-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-03-14
- Letzte Einreichung: 2019-02-28
-
BRIDGE COURT (FARNHAM) LIMITED Firmenbeschreibung
- BRIDGE COURT (FARNHAM) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06517015. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.02.2008 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68320" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.02.2013.Die Firma kann schriftlich über Newtown House erreicht werden.
Jetzt sichern BRIDGE COURT (FARNHAM) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bridge Court (Farnham) Limited - Newtown House, 38 Newtown Road, Liphook, Hampshire, Grossbritannien
- 2008-02-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BRIDGE COURT (FARNHAM) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-26) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-15) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-15) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-09) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-09) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-01) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-20) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2014-03-20) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-24) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-12) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-05-16) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-23) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-06-28) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2012-06-28) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2012-06-28) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2012-03-19) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-02-18) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-04-16) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-03-25) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-03-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-15) - 363a
-
legacy (2009-05-29) - 288a
-
legacy (2009-05-29) - 288b
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2009-12-30) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-09-02) - 88(2)
-
legacy (2008-03-06) - 288b
-
legacy (2008-03-08) - 288a
-
legacy (2008-05-24) - 395
-
legacy (2008-09-04) - 88(2)
-
legacy (2008-11-10) - 88(2)
-
legacy (2008-10-01) - 88(2)
-
legacy (2008-10-17) - 88(2)
-
legacy (2008-11-04) - 88(2)
-
legacy (2008-11-18) - 88(2)
-
legacy (2008-09-30) - 88(2)
-
incorporation-company (2008-02-28) - NEWINC