-
TOTAL NEGOTIATION LIMITED - Team House, 1 Fairview Estate, Henley-On-Thames, Oxfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06859459
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Team House
- 1 Fairview Estate
- Henley-On-Thames
- Oxfordshire
- RG9 1HE
- United Kingdom Team House, 1 Fairview Estate, Henley-On-Thames, Oxfordshire, RG9 1HE, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CRANSTOUN, Mark John Simon
- GRICE, Mark Jonathan
- ALLDER, Dean Lawrence John
- Prokuristen
- CRANSTOUN, Mark John Simon
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.03.2009
- Alter der Firma 2009-03-26 15 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Total Negotiation Trustees Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 21380012DCG37P5WO898
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-03-26
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-04-09
- Letzte Einreichung: 2022-03-26
-
TOTAL NEGOTIATION LIMITED Firmenbeschreibung
- TOTAL NEGOTIATION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06859459. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.03.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 26.03.2013.Die Firma kann schriftlich über Team House erreicht werden.
Jetzt sichern TOTAL NEGOTIATION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Total Negotiation Limited - Team House, 1 Fairview Estate, Henley-On-Thames, Oxfordshire, Grossbritannien
- 2009-03-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TOTAL NEGOTIATION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-04-29) - CS01
-
resolution (2022-03-16) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2022-03-16) - MA
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2022-03-15) - SH10
-
capital-name-of-class-of-shares (2022-03-15) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-03-22) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-03-14) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2022-03-14) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-03-14) - PSC02
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-24) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-06-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-26) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-31) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-03-31) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-19) - AP01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-05) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-18) - PSC04
-
resolution (2019-06-08) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-20) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-20) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-03) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-03) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-03) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-03-22) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-17) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-19) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-10-18) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-alter-shares-subdivision (2017-05-19) - SH02
-
resolution (2017-06-21) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2017-06-21) - MA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-19) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-15) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-22) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-04-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-12-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-20) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-20) - CH01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-03-26) - NEWINC