-
ACIS TRANSPORT LIABILITY AGENCY SERVICES LTD. - 8 Northumberland Gardens, Bickley, BR1 2XD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 06985963
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 8 Northumberland Gardens
- Bickley
- BR1 2XD 8 Northumberland Gardens, Bickley, BR1 2XD UK
Management
- Geschäftsführung
- HUGHES, Kevin Barry
- Prokuristen
- SIMPSON, Victoria Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.08.2009
- Gelöscht am:
- 2023-12-19
- SIC/NACE
- 65120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Acis Cargo Underwriting Agency Ltd
- Acis Underwriting Agencies Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-08-24
- Letzte Einreichung: 2022-08-10
-
ACIS TRANSPORT LIABILITY AGENCY SERVICES LTD. Firmenbeschreibung
- ACIS TRANSPORT LIABILITY AGENCY SERVICES LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 06985963. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.08.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "65120" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 8 Northumberland Gardens erreicht werden.
Jetzt sichern ACIS TRANSPORT LIABILITY AGENCY SERVICES LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Acis Transport Liability Agency Services Ltd. - 8 Northumberland Gardens, Bickley, BR1 2XD, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ACIS TRANSPORT LIABILITY AGENCY SERVICES LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-15) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-06-15) - PSC05
-
resolution (2023-07-27) - RESOLUTIONS
-
legacy (2023-07-27) - CAP-SS
-
legacy (2023-07-27) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2023-07-27) - SH19
-
dissolution-application-strike-off-company (2023-09-20) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2023-10-03) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-03) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-26) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-26) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-23) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-24) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-07-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-06-17) - AA
-
termination-director-company-with-name (2014-01-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-05-28) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-04) - AA
-
termination-secretary-company-with-name (2013-04-12) - TM02
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-04) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-08-16) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-05-11) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2011-04-19) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-09-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-08-10) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-18) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-03) - AP01
-
legacy (2009-09-16) - 88(2)
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2009-10-15) - AP03