-
ZEPHYRAM LIMITED - 3 Lansdowne Terrace, Devizes, SN10 1NX, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07104559
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 Lansdowne Terrace
- Devizes
- SN10 1NX
- England 3 Lansdowne Terrace, Devizes, SN10 1NX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MCNEILE, Henrietta Cecilia Imogen
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.12.2009
- Alter der Firma 2009-12-15 14 Jahre
- SIC/NACE
- 66190
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Avoncourt Property Investments Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- A & M FINANCIAL SERVICES LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-15
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-07
- Letzte Einreichung: 2023-03-24
-
ZEPHYRAM LIMITED Firmenbeschreibung
- ZEPHYRAM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07104559. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.12.2009 registriert. ZEPHYRAM LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen A & M FINANCIAL SERVICES LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "66190" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/12/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 15.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 3 Lansdowne Terrace erreicht werden.
Jetzt sichern ZEPHYRAM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Zephyram Limited - 3 Lansdowne Terrace, Devizes, SN10 1NX, England, Grossbritannien
- 2009-12-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ZEPHYRAM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-24) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2023-03-17) - AA01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-03-22) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-03-24) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-03-24) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-03-23) - PSC04
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-10-25) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-12-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-08-16) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-14) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-08-20) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-07-11) - AA
-
resolution (2018-02-28) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-26) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-26) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-26) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-26) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
court-order (2017-11-14) - OC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-05) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-10-17) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-08-25) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-22) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-28) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-23) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-02-12) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2014-02-12) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-01-15) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-16) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-01-23) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-21) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-06-13) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-12-21) - AR01
-
capital-allotment-shares (2010-08-11) - SH01
keyboard_arrow_right 2009
-
appoint-person-director-company-with-name (2009-12-22) - AP01
-
incorporation-company (2009-12-15) - NEWINC