-
GARMENT QUARTER LIMITED - #153 179 Whiteladies Road, Clifton, Bristol, BS8 2AG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07128387
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- #153 179 Whiteladies Road
- Clifton
- Bristol
- BS8 2AG
- England #153 179 Whiteladies Road, Clifton, Bristol, BS8 2AG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.01.2010
- Gelöscht am:
- 2021-12-20
- SIC/NACE
- 47710
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Reid
- Mr Peter Graham Lake
- Mr John Reid
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- ZAGAL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2013-09-30
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-18
-
GARMENT QUARTER LIMITED Firmenbeschreibung
- GARMENT QUARTER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07128387. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 18.01.2010 registriert. GARMENT QUARTER LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ZAGAL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47710" registriert. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.01.2013.Die Firma kann schriftlich über #153 179 Whiteladies Road erreicht werden.
Jetzt sichern GARMENT QUARTER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Garment Quarter Limited - #153 179 Whiteladies Road, Clifton, Bristol, BS8 2AG, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GARMENT QUARTER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-liquidation (2021-12-20) - GAZ2
-
liquidation-compulsory-completion (2021-09-20) - L64.07
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-compulsory-winding-up-order (2020-01-22) - COCOMP
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-12-30) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-30) - TM01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-12-12) - DISS16(SOAS)
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-03) - AD01
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-03) - GAZ1
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-04) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-07) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-10-04) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-10) - AA
-
resolution (2018-03-26) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-26) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-21) - CS01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2018-04-20) - SH10
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-27) - CS01
-
resolution (2017-02-24) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-05-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-06) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-05-05) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-10-26) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-26) - MR01
-
mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2015-08-07) - MR05
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-06-03) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-02) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-03-26) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-19) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-03-19) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-27) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-09) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-09-24) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-11) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-03-11) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-03-10) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-02-28) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-24) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-03-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2012
-
legacy (2012-07-19) - MG01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-27) - AA
-
legacy (2011-07-22) - MG01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-03) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2011-01-04) - AA01
keyboard_arrow_right 2010
-
legacy (2010-09-13) - MG01
-
legacy (2010-07-22) - MG01
-
incorporation-company (2010-01-18) - NEWINC