-
MY SURGERY WEBSITE LIMITED - Indigo House, Sussex Avenue, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07214802
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Indigo House
- Sussex Avenue
- Leeds
- West Yorkshire
- LS10 2LF Indigo House, Sussex Avenue, Leeds, West Yorkshire, LS10 2LF UK
Management
- Geschäftsführung
- GINNETTI, Daniel V
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.04.2010
- Gelöscht am:
- 2021-11-30
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Srcl Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-04-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-21
- Letzte Einreichung: 2021-04-07
-
MY SURGERY WEBSITE LIMITED Firmenbeschreibung
- MY SURGERY WEBSITE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07214802. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 07.04.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/04/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.04.2012.Die Firma kann schriftlich über Indigo House erreicht werden.
Jetzt sichern MY SURGERY WEBSITE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: My Surgery Website Limited - Indigo House, Sussex Avenue, Leeds, West Yorkshire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MY SURGERY WEBSITE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-11-30) - GAZ2(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-09-03) - DS01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-08-23) - SH19
-
legacy (2021-08-23) - SH20
-
resolution (2021-08-23) - RESOLUTIONS
-
legacy (2021-08-23) - CAP-SS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-16) - CS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-09-14) - GAZ1(A)
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-10-12) - SOAS(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-10-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-05-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-16) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-03-14) - AP01
-
resolution (2019-03-07) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-03-04) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-07-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-20) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-06) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-06-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-09-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-25) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2014-04-01) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-09-04) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-06-10) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2013-02-26) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-01-03) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-04-11) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-11) - AR01
-
capital-allotment-shares (2012-10-12) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2012-10-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-10-29) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-08-28) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-19) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-12) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-09) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-05-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-04-07) - NEWINC