-
WHITE ROSE DENTAL PRACTICE LTD - The Summit Woodwater Park, Pynes Hill, Exeter, Devon, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07257604
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Summit Woodwater Park
- Pynes Hill
- Exeter
- Devon
- EX2 5WS
- United Kingdom The Summit Woodwater Park, Pynes Hill, Exeter, Devon, EX2 5WS, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- SMITH, Simon Druce
- Prokuristen
- SMITH, Lucy Isabelle
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.05.2010
- Alter der Firma 2010-05-18 14 Jahre
- SIC/NACE
- 86230
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Druce Smith
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-04-30
- Letzte Einreichung: 2023-07-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-05-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-06-01
- Letzte Einreichung: 2024-05-18
-
WHITE ROSE DENTAL PRACTICE LTD Firmenbeschreibung
- WHITE ROSE DENTAL PRACTICE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07257604. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.05.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86230" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/07/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.05.2012.Die Firma kann schriftlich über The Summit Woodwater Park erreicht werden.
Jetzt sichern WHITE ROSE DENTAL PRACTICE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: White Rose Dental Practice Ltd - The Summit Woodwater Park, Pynes Hill, Exeter, Devon, Grossbritannien
- 2010-05-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WHITE ROSE DENTAL PRACTICE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-04-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-05-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-11-03) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-04-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-05-22) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-06-23) - MR04
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2023-11-03) - CH03
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-24) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-07) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-27) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-26) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-11) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-03) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-11-14) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-19) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-23) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-13) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-04-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-15) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-25) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-04) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-27) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-05-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-06-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-15) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-06-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-12-13) - AA01
-
incorporation-company (2010-05-18) - NEWINC