-
HEATING CENTRAL LIMITED - 3 The Courtyard Harris Business Prk Hanbury Road, Stoke Prior, Bromsgrove, B60 4DJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07292443
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 The Courtyard Harris Business Prk Hanbury Road
- Stoke Prior
- Bromsgrove
- B60 4DJ 3 The Courtyard Harris Business Prk Hanbury Road, Stoke Prior, Bromsgrove, B60 4DJ UK
Management
- Geschäftsführung
- PORTER, David Benjamin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.06.2010
- Gelöscht am:
- 2020-04-10
- SIC/NACE
- 43220
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2015-03-31
-
HEATING CENTRAL LIMITED Firmenbeschreibung
- HEATING CENTRAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07292443. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 22.06.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43220" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3 The Courtyard Harris Business Prk Hanbury Road erreicht werden.
Jetzt sichern HEATING CENTRAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Heating Central Limited - 3 The Courtyard Harris Business Prk Hanbury Road, Stoke Prior, Bromsgrove, B60 4DJ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HEATING CENTRAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-04-10) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2020-01-10) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-01-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-01-09) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-11) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs-with-form-attached (2016-11-08) - 4.20
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2016-11-08) - 600
-
resolution (2016-11-08) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-20) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-22) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-09) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-14) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-04) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-08) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-14) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-01-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2013-11-29) - RP04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-06-27) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2013-01-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-20) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-14) - AA
-
termination-director-company-with-name (2012-08-03) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-07-23) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-02-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2011
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2011-12-19) - AA
-
capital-allotment-shares (2011-10-20) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-07-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2010-11-19) - AA01
-
incorporation-company (2010-06-22) - NEWINC