-
UCS RENEWABLES LIMITED - 3a Brighouse Business Village, Brighouse Road, Middlesbrough, Cleveland, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07352484
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3a Brighouse Business Village
- Brighouse Road
- Middlesbrough
- Cleveland
- TS2 1RT
- England 3a Brighouse Business Village, Brighouse Road, Middlesbrough, Cleveland, TS2 1RT, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CLOSE, Colin Simon
- KIDD, Paul Anthony
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.08.2010
- Alter der Firma 2010-08-20 14 Jahre
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Colin Simon Close
- Mr Paul Anthony Kidd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-08-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-23
- Letzte Einreichung: 2024-01-09
-
UCS RENEWABLES LIMITED Firmenbeschreibung
- UCS RENEWABLES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07352484. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.08.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/08/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.08.2012.Die Firma kann schriftlich über 3A Brighouse Business Village erreicht werden.
Jetzt sichern UCS RENEWABLES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ucs Renewables Limited - 3a Brighouse Business Village, Brighouse Road, Middlesbrough, Cleveland, Grossbritannien
- 2010-08-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu UCS RENEWABLES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-01-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-02-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-06-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-10-23) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-09) - AA
-
capital-cancellation-shares (2016-12-08) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2016-12-08) - SH03
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-12) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-05-11) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-16) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-11-05) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-09-29) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-28) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-11) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-09-04) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-14) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-29) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-12-20) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-17) - AR01
-
gazette-notice-compulsary (2014-12-16) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-01-16) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-20) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2012-07-10) - AA
-
legacy (2012-03-07) - MG01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-02) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-04-21) - CH01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-08-20) - NEWINC