-
LIQUID ASSOCIATES LIMITED - Stockton House, Stockton, Newport, Shropshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07373423
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Stockton House
- Stockton
- Newport
- Shropshire
- TF10 9BA
- England Stockton House, Stockton, Newport, Shropshire, TF10 9BA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DRISCOLL, Christopher Alexander
- DRISCOLL, Darren Anthony
- MAJOR, Jamie Eric
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-13 14 Jahre
- SIC/NACE
- 77110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Liquid Fleet Holdings Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-05-15
- Letzte Einreichung: 2019-05-01
-
LIQUID ASSOCIATES LIMITED Firmenbeschreibung
- LIQUID ASSOCIATES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07373423. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.09.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "77110" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/12/2011 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Stockton House erreicht werden.
Jetzt sichern LIQUID ASSOCIATES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Liquid Associates Limited - Stockton House, Stockton, Newport, Shropshire, Grossbritannien
- 2010-09-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LIQUID ASSOCIATES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-02-28) - DS01
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-06) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-06) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-08) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-10-08) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-08) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-12) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-11) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-11) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-11) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-12-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-27) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-09-23) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-05) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-09-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-05-13) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-10) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-24) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-30) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-11-30) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-09-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-01) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-03-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-12-03) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2010-12-02) - AA01
-
incorporation-company (2010-09-13) - NEWINC