-
WHEELER HOMES LIMITED - Four Tai Tywyn Business Centre, Glan - Y - Gors, Prestatyn, Denbighshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07380546
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Four Tai Tywyn Business Centre
- Glan - Y - Gors
- Prestatyn
- Denbighshire
- LL19 7SF Four Tai Tywyn Business Centre, Glan - Y - Gors, Prestatyn, Denbighshire, LL19 7SF UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIES, Rhys
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.09.2010
- Alter der Firma 2010-09-17 14 Jahre
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Rhys Davies
- Mrs Jacky Davies
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-31
- Letzte Einreichung: 2019-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-09-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-01
- Letzte Einreichung: 2020-09-17
-
WHEELER HOMES LIMITED Firmenbeschreibung
- WHEELER HOMES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07380546. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.09.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30/09/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.09.2012.Die Firma kann schriftlich über Four Tai Tywyn Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern WHEELER HOMES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Wheeler Homes Limited - Four Tai Tywyn Business Centre, Glan - Y - Gors, Prestatyn, Denbighshire, Grossbritannien
- 2010-09-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu WHEELER HOMES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-06-11) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2021-06-08) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-09) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-03-27) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-11-10) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-11-10) - PSC09
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-27) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-06-19) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-03-22) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-12-11) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-03-16) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-06-11) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-09-27) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-01) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-31) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-09) - MR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-24) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-12-21) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-12) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-03-08) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-02-28) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-13) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-03-29) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-05) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-26) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-02) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-21) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-23) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-14) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-12-31) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-31) - AP01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-16) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-06-18) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-06-12) - AA01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-10-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2011-10-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-09-17) - NEWINC