-
CHBC INVESTMENTS LIMITED - Third Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07433748
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Third Floor
- 207 Regent Street
- London
- W1B 3HH Third Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH UK
Management
- Geschäftsführung
- STOKES, Warren Victor
- NEILSON, Moya
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-09 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Ms Moya Neilson
- Mr Warren Stokes
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-11-09
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-23
- Letzte Einreichung: 2023-11-09
-
CHBC INVESTMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- CHBC INVESTMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07433748. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.11.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68202" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 09.11.2012.Die Firma kann schriftlich über Third Floor erreicht werden.
Jetzt sichern CHBC INVESTMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Chbc Investments Limited - Third Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH, Grossbritannien
- 2010-11-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHBC INVESTMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-10-03) - AP01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-10-03) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-10-03) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2023-10-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-11-09) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-10-03) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-10-03) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-09-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-19) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-17) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-21) - AAMD
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-06) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-19) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-11-19) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-14) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-02-09) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-27) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-02-01) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-13) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-13) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-21) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-16) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-16) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2013-06-05) - AA01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-11-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-08) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-11-29) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-11-03) - AD01
-
legacy (2011-03-03) - MG01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-09) - NEWINC