-
BPC FINANCE & LEASING LIMITED - Ferndale House 3 Firs Street, Dudley, West Midlands, DY2 7DN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07440215
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ferndale House 3 Firs Street
- Dudley
- West Midlands
- DY2 7DN Ferndale House 3 Firs Street, Dudley, West Midlands, DY2 7DN UK
Management
- Geschäftsführung
- ALLPORT, Peter Mathew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 15.11.2010
- Alter der Firma 2010-11-15 13 Jahre
- SIC/NACE
- 45111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Peter Mathew Allport
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-08-31
- Letzte Einreichung: 2022-11-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-10
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-05-12
- Letzte Einreichung: 2024-04-28
-
BPC FINANCE & LEASING LIMITED Firmenbeschreibung
- BPC FINANCE & LEASING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07440215. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 15.11.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45111" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 10.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Ferndale House 3 Firs Street erreicht werden.
Jetzt sichern BPC FINANCE & LEASING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bpc Finance & Leasing Limited - Ferndale House 3 Firs Street, Dudley, West Midlands, DY2 7DN, Grossbritannien
- 2010-11-15
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BPC FINANCE & LEASING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-notice-compulsory (2024-07-16) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-07-26) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2024-07-27) - DISS40
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-08-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-08-25) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-26) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-26) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-09) - AR01
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2016-06-09) - AD02
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-17) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-07-17) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-28) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-04-28) - AP03
-
change-sail-address-company (2014-04-28) - AD02
-
termination-secretary-company-with-name (2014-04-28) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2014-04-28) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-07-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-11-15) - NEWINC