-
EXCEL MODULAR BUILDINGS LIMITED - Office 31/33 Craven Park Enterprise Park, Preston Road, Hull, HU9 5HE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07502037
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Office 31/33 Craven Park Enterprise Park
- Preston Road
- Hull
- HU9 5HE
- England Office 31/33 Craven Park Enterprise Park, Preston Road, Hull, HU9 5HE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COYNE, Lisa Janye
- Prokuristen
- COYNE, Lisa Jayne
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.01.2011
- Alter der Firma 2011-01-21 13 Jahre
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Dennis Francis Waller
- Mrs Sheila Waller
- Mrs Sheila Waller
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-10-31
- Letzte Einreichung: 2021-01-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-01-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-21
- Letzte Einreichung: 2020-12-07
-
EXCEL MODULAR BUILDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- EXCEL MODULAR BUILDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07502037. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.01.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/01/2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 31.01.2013.Die Firma kann schriftlich über Office 31/33 Craven Park Enterprise Park erreicht werden.
Jetzt sichern EXCEL MODULAR BUILDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Excel Modular Buildings Limited - Office 31/33 Craven Park Enterprise Park, Preston Road, Hull, HU9 5HE, Grossbritannien
- 2011-01-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EXCEL MODULAR BUILDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-26) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-11-18) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-11-18) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-01) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-25) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-16) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-08) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-27) - AA
-
notice-restriction-on-company-articles (2015-07-28) - CC01
-
resolution (2015-07-28) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-08) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-08-05) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-09) - AR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-07-28) - SH08
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-secretary-company-with-name (2014-02-03) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-03) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-02-03) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-04-26) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-02-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-02-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-01-25) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-01-25) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name (2011-01-25) - TM02
-
legacy (2011-02-15) - MG01
-
resolution (2011-02-15) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-02-15) - AP01
-
capital-allotment-shares (2011-02-15) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2011-02-17) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-23) - AD01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2011-03-30) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-03-30) - CH01
-
incorporation-company (2011-01-21) - NEWINC