-
AUTOBASE (GB) LIMITED - Premier Suite, 4 Churchill Court 58 Station Road, North Harrow, HA2 7ST, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07531773
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Premier Suite
- 4 Churchill Court 58 Station Road
- North Harrow
- HA2 7ST Premier Suite, 4 Churchill Court 58 Station Road, North Harrow, HA2 7ST UK
Management
- Geschäftsführung
- ALLIBHAI, Murtaza
- ALLIBHAI, Sibtain
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.02.2011
- Alter der Firma 2011-02-16 13 Jahre
- SIC/NACE
- 45111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Murtaza Allibhai
- Mr Sibtain Allibhai
- Mr Sibtain Allibhai
- Mr Murtaza Allibhai
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-27
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-27
- Letzte Einreichung: 2023-04-13
-
AUTOBASE (GB) LIMITED Firmenbeschreibung
- AUTOBASE (GB) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07531773. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.02.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 27.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Premier Suite erreicht werden.
Jetzt sichern AUTOBASE (GB) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Autobase (Gb) Limited - Premier Suite, 4 Churchill Court 58 Station Road, North Harrow, HA2 7ST, Grossbritannien
- 2011-02-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AUTOBASE (GB) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-12) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-09) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-16) - AAMD
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-04) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-08-26) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-21) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-12) - AA
-
resolution (2019-03-06) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2019-02-26) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-31) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-04) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-03-04) - CH01
-
termination-director-company (2015-03-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-05) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-12-01) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-27) - AR01
-
termination-director-company-with-name (2012-04-27) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2012-04-30) - TM01
-
capital-allotment-shares (2012-05-02) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-19) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-04-27) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-11-19) - CH01
-
termination-director-company-with-name (2012-12-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-27) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-04-19) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-02-17) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2011-06-23) - AA01
-
capital-allotment-shares (2011-05-23) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-05-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2011-02-17) - TM01
-
incorporation-company (2011-02-16) - NEWINC