-
VINCENT GLASGOW 2017 LIMITED - 26-28 Bedford Row, London, WC1R 4HE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07680242
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 26-28 Bedford Row
- London
- WC1R 4HE 26-28 Bedford Row, London, WC1R 4HE UK
Management
- Geschäftsführung
- TOLLEY, Thomas Mark
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.06.2011
- Alter der Firma 2011-06-23 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Barry Sternlicht
- Barry Sternlicht
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- ABSTRACT (GLASGOW) LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-07-09
- Letzte Einreichung: 2017-10-09
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-08-03
- Letzte Einreichung: 2018-07-20
-
VINCENT GLASGOW 2017 LIMITED Firmenbeschreibung
- VINCENT GLASGOW 2017 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07680242. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.06.2011 registriert. VINCENT GLASGOW 2017 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ABSTRACT (GLASGOW) LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 23.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 26-28 Bedford Row erreicht werden.
Jetzt sichern VINCENT GLASGOW 2017 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vincent Glasgow 2017 Limited - 26-28 Bedford Row, London, WC1R 4HE, Grossbritannien
- 2011-06-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VINCENT GLASGOW 2017 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-09-17) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-28) - TM01
-
resolution (2019-07-17) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-07-17) - LIQ01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-11-05) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-07-18) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-07-17) - 600
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-23) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-28) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-06-28) - PSC09
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2018-02-02) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2018-02-02) - AD02
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-02) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-31) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-10-31) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-31) - AD01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2017-10-31) - AP04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-10-31) - TM02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-31) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-11-01) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-02) - MR01
-
certificate-change-of-name-company (2017-11-17) - CERTNM
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-11-01) - PSC08
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-10-16) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-07-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-04-19) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-07-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-04-07) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-03) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-06-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-25) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-15) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2014-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-05-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-16) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-30) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-07-17) - AR01
-
capital-allotment-shares (2013-08-09) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-13) - MR01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-08-09) - SH02
-
resolution (2013-12-09) - RESOLUTIONS
-
resolution (2013-08-09) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-small (2012-09-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-07-11) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2012-05-04) - AP03
keyboard_arrow_right 2011
-
termination-director-company-with-name (2011-12-05) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-11-28) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-11-07) - AP01
-
incorporation-company (2011-06-23) - NEWINC