-
LIVERTON BUSINESS PARK 2011 LIMITED - Centenary House Peninsula Park, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07712161
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Centenary House Peninsula Park
- Rydon Lane
- Exeter
- EX2 7XE
- United Kingdom Centenary House Peninsula Park, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- COBB, David John
- RIX, Leigh Stuart
- VARLEY, John Christian
- WILDING, William John
- WOOD, Jonathan Lucas Singleton
- Prokuristen
- VANSTONE, Graham Edward
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.07.2011
- Alter der Firma 2011-07-20 13 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Michael Chamberlayne Lvo
- David James Roper Robinson
- Edward Charles Fane Trefusis
- Mr Noel George Herbert Manns
- -
- David James Roper Robinson
- Edward Charles Fane Trefusis
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-08-03
- Letzte Einreichung: 2022-07-20
-
LIVERTON BUSINESS PARK 2011 LIMITED Firmenbeschreibung
- LIVERTON BUSINESS PARK 2011 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07712161. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.07.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2012 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Centenary House Peninsula Park erreicht werden.
Jetzt sichern LIVERTON BUSINESS PARK 2011 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Liverton Business Park 2011 Limited - Centenary House Peninsula Park, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, Grossbritannien
- 2011-07-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LIVERTON BUSINESS PARK 2011 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-07) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-07-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-22) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-03) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-03) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-09-01) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-30) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-07-30) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-11) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-30) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-01-20) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-08) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-01-20) - AP03
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-11) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-12) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-08-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-18) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-name-of-class-of-shares (2012-02-14) - SH08
-
resolution (2012-03-05) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2012-02-14) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-09-11) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-08-01) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-07-20) - NEWINC
-
change-person-director-company-with-change-date (2011-08-03) - CH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2011-07-26) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-07-26) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2011-07-26) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2011-07-25) - TM01