-
G & L DUCTWORK LTD - 1 Radian Court, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PJ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07806023
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 Radian Court
- Knowlhill
- Milton Keynes
- MK5 8PJ 1 Radian Court, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PJ UK
Management
- Geschäftsführung
- RUSSELL, Gary John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-11 12 Jahre
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-07-31
- Letzte Einreichung: 2016-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-10-25
- Letzte Einreichung: 2017-10-11
-
G & L DUCTWORK LTD Firmenbeschreibung
- G & L DUCTWORK LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07806023. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1 Radian Court erreicht werden.
Jetzt sichern G & L DUCTWORK LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: G & L Ductwork Ltd - 1 Radian Court, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PJ, Grossbritannien
- 2011-10-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu G & L DUCTWORK LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2024-06-15) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2024-06-15) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-12-08) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-12-14) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-05-19) - PSC07
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-12-08) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-12-07) - LIQ03
-
capital-cancellation-shares (2020-11-23) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-11-23) - SH03
-
capital-allotment-shares (2020-11-09) - SH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-10-19) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-11-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-disclaimer-notice (2018-12-07) - NDISC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-21) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2018-10-24) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-10-24) - 600
-
resolution (2018-10-24) - RESOLUTIONS
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-10-09) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2018-10-02) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-13) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-13) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-31) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-09-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-28) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-07-10) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2013-03-02) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-03-01) - CH01
-
gazette-notice-compulsary (2013-02-05) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2012
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-10-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-10-11) - NEWINC