-
S & S CONSULTING SERVICES (UK) LIMITED - Onega House, 112 Main Road, Sidcup, Kent, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07812885
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Onega House
- 112 Main Road
- Sidcup
- Kent
- DA14 6NE Onega House, 112 Main Road, Sidcup, Kent, DA14 6NE UK
Management
- Geschäftsführung
- BROOKFIELD, Joanne Louise
- HILL, Spencer George
- Prokuristen
- DYER + CO SECRETARIAL SERVICES LTD
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.10.2011
- Alter der Firma 2011-10-17 12 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Spencer George Hill
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-07-31
- Letzte Einreichung: 2022-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-04-27
- Letzte Einreichung: 2022-04-13
-
S & S CONSULTING SERVICES (UK) LIMITED Firmenbeschreibung
- S & S CONSULTING SERVICES (UK) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07812885. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.10.2011 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Onega House erreicht werden.
Jetzt sichern S & S CONSULTING SERVICES (UK) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: S & S Consulting Services (Uk) Limited - Onega House, 112 Main Road, Sidcup, Kent, Grossbritannien
- 2011-10-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu S & S CONSULTING SERVICES (UK) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-04-13) - AA
-
resolution (2023-05-01) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2023-05-01) - MA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-04-05) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2023-05-01) - SH08
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-12-17) - MR04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-06-02) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-13) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-05) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-15) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-10-29) - MR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-22) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-02-21) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-07-27) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-07-11) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-11-28) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-15) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-19) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-21) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-07) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-16) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-17) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-15) - AR01
-
capital-alter-shares-consolidation (2014-08-30) - SH02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-10-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2013-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-12-13) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-10-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
incorporation-company (2011-10-17) - NEWINC