-
PARKEGATE LIMITED - 40-41 The Bridge Business Centre, Beresford Way, Chesterfield, S41 9FG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07939534
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 40-41 The Bridge Business Centre
- Beresford Way
- Chesterfield
- S41 9FG 40-41 The Bridge Business Centre, Beresford Way, Chesterfield, S41 9FG UK
Management
- Geschäftsführung
- LIDGATE, Stephen David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-07 12 Jahre
- SIC/NACE
- 25110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Sms Group Gmbh
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-02-07
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-11
- Letzte Einreichung: 2023-01-28
-
PARKEGATE LIMITED Firmenbeschreibung
- PARKEGATE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07939534. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "25110" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 07.02.2013.Die Firma kann schriftlich über 40-41 The Bridge Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern PARKEGATE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Parkegate Limited - 40-41 The Bridge Business Centre, Beresford Way, Chesterfield, S41 9FG, Grossbritannien
- 2012-02-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PARKEGATE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-02-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-05-16) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-08-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-16) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-06) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-13) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-10-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-01) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-13) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-16) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-04) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-01-04) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-22) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-10-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-02-02) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-24) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-small (2013-09-06) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-03-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-11-21) - AP01
-
legacy (2012-06-13) - MG01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-05-24) - AP01
-
capital-alter-shares-consolidation (2012-05-24) - SH02
-
capital-allotment-shares (2012-05-24) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2012-03-21) - AA01
-
incorporation-company (2012-02-07) - NEWINC