-
SISP TECHNOLOGIES LTD - 47 Albemarle Street, London, W1S 4JW, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07963249
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 47 Albemarle Street
- London
- W1S 4JW
- England 47 Albemarle Street, London, W1S 4JW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MARLOW, Stuart James
- STAVRINOU, Nicholas James
- Prokuristen
- STAVRINOU, Catherine Mary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.02.2012
- Alter der Firma 2012-02-24 12 Jahre
- SIC/NACE
- 74909
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nicholas James Stavrinou
- Dover Street Restaurant Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-10
- Letzte Einreichung: 2021-02-24
-
SISP TECHNOLOGIES LTD Firmenbeschreibung
- SISP TECHNOLOGIES LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07963249. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.02.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "74909" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 47 Albemarle Street erreicht werden.
Jetzt sichern SISP TECHNOLOGIES LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sisp Technologies Ltd - 47 Albemarle Street, London, W1S 4JW, England, Grossbritannien
- 2012-02-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SISP TECHNOLOGIES LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-11) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-02-26) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-12) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-07) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-19) - AA
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2019-03-06) - AD03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-06) - CS01
-
change-sail-address-company-with-new-address (2019-03-06) - AD02
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-26) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-12-10) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-12) - AA
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2018-01-15) - RP04AR01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-21) - PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-21) - PSC04
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-21) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-03-21) - PSC09
-
capital-allotment-shares (2018-01-19) - SH01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-21) - AP01
-
capital-allotment-shares (2017-08-10) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-07) - CS01
-
resolution (2017-07-18) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-12-09) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-09) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-12-09) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-24) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-03-17) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-17) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-09-22) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-26) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-14) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-08) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2013-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-02-24) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-04-05) - AP01