-
SONIC DRILLING & PILING PLANTHIRE LIMITED - Spring Lodge 172 Chester Road, Helsby, Cheshire, WA6 0AR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 07981593
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Spring Lodge 172 Chester Road
- Helsby
- Cheshire
- WA6 0AR
- England Spring Lodge 172 Chester Road, Helsby, Cheshire, WA6 0AR, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CHRISTIE, Kevin Alexander
- LEWIS, Graham William
- WHINFIELD, Paul Stuart
- WOODFIELD, Paul
- DRAPER, Abigail Sarah
- KNIGHTON, Claire
- RYDER, Alasdair Alan
- TUCKWELL, George William
- Prokuristen
- EVANS, Sally
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.03.2012
- Alter der Firma 2012-03-08 12 Jahre
- SIC/NACE
- 43999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Paul Woodfield
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-22
- Letzte Einreichung: 2021-03-08
-
SONIC DRILLING & PILING PLANTHIRE LIMITED Firmenbeschreibung
- SONIC DRILLING & PILING PLANTHIRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 07981593. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.03.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43999" registriert. Das Unternehmen hat 8 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Spring Lodge 172 Chester Road erreicht werden.
Jetzt sichern SONIC DRILLING & PILING PLANTHIRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sonic Drilling & Piling Planthire Limited - Spring Lodge 172 Chester Road, Helsby, Cheshire, WA6 0AR, Grossbritannien
- 2012-03-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SONIC DRILLING & PILING PLANTHIRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-02) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-07-02) - PSC07
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-07-02) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-10) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-07-03) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-20) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-01-04) - SH08
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-cancellation-shares (2015-02-13) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2015-02-13) - SH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-19) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-30) - AA
-
resolution (2015-08-19) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-08-19) - SH08
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-cancellation-shares (2014-12-09) - SH06
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-15) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2014-12-09) - SH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-04-04) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-04) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-11-11) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-11) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-07) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-03-08) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-08-30) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-08-17) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2012-07-31) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-07-03) - AD01