-
TRANS ECO MINERALS AND MINING LTD - Sk House 143e Arthur Road, Suite 228, Windsor, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08191274
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Sk House 143e Arthur Road
- Suite 228
- Windsor
- Berkshire
- SL4 1SE
- England Sk House 143e Arthur Road, Suite 228, Windsor, Berkshire, SL4 1SE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- AMARH, Godwin Nickleson
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.08.2012
- Alter der Firma 2012-08-24 12 Jahre
- SIC/NACE
- 08990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Mr Godwin Nickleson Amarh
- Kazzr Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-30
- Letzte Einreichung: 2020-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-07
- Letzte Einreichung: 2021-08-24
-
TRANS ECO MINERALS AND MINING LTD Firmenbeschreibung
- TRANS ECO MINERALS AND MINING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08191274. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.08.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "08990" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Sk House 143E Arthur Road erreicht werden.
Jetzt sichern TRANS ECO MINERALS AND MINING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Trans Eco Minerals And Mining Ltd - Sk House 143e Arthur Road, Suite 228, Windsor, Berkshire, Grossbritannien
- 2012-08-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TRANS ECO MINERALS AND MINING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-05-27) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-09-03) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-08-26) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-09-03) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-09-03) - PSC07
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-05-29) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-17) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-17) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-17) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-02-20) - AP01
-
capital-allotment-shares (2019-09-26) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-05-29) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-08-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-08-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-10) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-05) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-09-05) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-05) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-04) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-08-03) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-08-02) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-08-01) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-05) - CS01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-18) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-26) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-12-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-12-15) - AP01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-10-22) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2015-08-25) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2015-02-07) - DISS16(SOAS)
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-12-16) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-12-15) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
gazette-notice-compulsory (2014-12-23) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-05-23) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-01-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-03-22) - TM01
-
termination-director-company-with-name (2013-10-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-22) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-11-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
incorporation-company (2012-08-24) - NEWINC