-
SMD ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED - Unit 4 Ridge House Ridge House Drive, Festival Park, Hanley, Stoke On Trent, Staffordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08415155
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 4 Ridge House Ridge House Drive
- Festival Park, Hanley
- Stoke On Trent
- Staffordshire
- ST1 5SJ
- England Unit 4 Ridge House Ridge House Drive, Festival Park, Hanley, Stoke On Trent, Staffordshire, ST1 5SJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CARSON, Steven
- FOX, Simon Neil
- POWELL, Neil
- ROBINSON, Luke
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.02.2013
- Alter der Firma 2013-02-22 11 Jahre
- SIC/NACE
- 43210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Matthew William Hassall
- Mr Steven Carson
- Mr Neil Powell
- Mr Simon Neil Fox
- Mr Luke Robinson
- Carson Powell Construction Ltd
- Mr Steven Carson
- Mr Neil Powell
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-10-05
- Letzte Einreichung: 2021-09-21
-
SMD ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED Firmenbeschreibung
- SMD ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08415155. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.02.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43210" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 4 Ridge House Ridge House Drive erreicht werden.
Jetzt sichern SMD ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Smd Electrical Contractors Limited - Unit 4 Ridge House Ridge House Drive, Festival Park, Hanley, Stoke On Trent, Staffordshire, Grossbritannien
- 2013-02-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SMD ELECTRICAL CONTRACTORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-15) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-02-24) - PSC01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-09-22) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-05-19) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-18) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-05-19) - SH08
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-29) - CS01
-
memorandum-articles (2020-05-19) - MA
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2020-05-19) - SH10
-
capital-alter-shares-subdivision (2020-05-19) - SH02
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-19) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-02-26) - PSC04
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-05) - AAMD
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-27) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-13) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-01) - MR01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-28) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-26) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-11) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-22) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-04-22) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-22) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-03-18) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-11-13) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-16) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-08-05) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2013-05-20) - TM01
-
incorporation-company (2013-02-22) - NEWINC