-
SFAM LIMITED - BEGBIES TRAYNOR, Suite Wg3 The Officers' Mess Business Centre Royston Road, Duxford, Cambridge, CB22 4QH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08430525
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- BEGBIES TRAYNOR
- Suite Wg3 The Officers' Mess Business Centre Royston Road, Duxford
- Cambridge
- CB22 4QH BEGBIES TRAYNOR, Suite Wg3 The Officers' Mess Business Centre Royston Road, Duxford, Cambridge, CB22 4QH UK
Management
- Geschäftsführung
- ARMAN, Darren Mark
- ARMAN, Katherine Glenys
- STEWART, John Neil
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-05 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Neil Stewart
- Mr Darren Mark Arman
- Mrs Katherine Glenys Arman
- Mr Nicholas Anthony Stewart
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- WINTRUST FINANCIAL SERVICES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-10-11
- Letzte Einreichung: 2021-01-11
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-16
- Letzte Einreichung: 2020-03-05
-
SFAM LIMITED Firmenbeschreibung
- SFAM LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08430525. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.03.2013 registriert. SFAM LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen WINTRUST FINANCIAL SERVICES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 11.01.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Begbies Traynor erreicht werden.
Jetzt sichern SFAM LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Sfam Limited - BEGBIES TRAYNOR, Suite Wg3 The Officers' Mess Business Centre Royston Road, Duxford, Cambridge, CB22 4QH, Grossbritannien
- 2013-03-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SFAM LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-03-20) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-03-16) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-12-07) - 600
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2022-12-07) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-17) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-20) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-01-20) - 600
-
resolution (2021-01-20) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2021-01-20) - LIQ01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-01-14) - AA01
keyboard_arrow_right 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-03-16) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-15) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-28) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-06-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-22) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-31) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-18) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-05) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-06-19) - SH01
-
termination-secretary-company-with-name (2014-06-20) - TM02
-
termination-director-company-with-name (2014-06-20) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-11-03) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-20) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
certificate-change-of-name-company (2013-08-29) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-08-29) - CONNOT
-
dissolution-withdrawal-application-strike-off-company (2013-08-15) - DS02
-
gazette-notice-voluntary (2013-07-16) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2013-07-03) - DS01
-
incorporation-company (2013-03-05) - NEWINC