-
NK STREAMLINE TRANSPORT LTD - 16 Didcot Road, Poole, Dorset, BH17 0GD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08436633
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 16 Didcot Road
- Poole
- Dorset
- BH17 0GD 16 Didcot Road, Poole, Dorset, BH17 0GD UK
Management
- Geschäftsführung
- SMITH, Nicola Karen
- TALUKDER, Rafik
- WHITE, Gary Roderick
- NICHOLLS, Kelly-Marie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-08 11 Jahre
- SIC/NACE
- 49320
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Trxcom Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-03-20
- Letzte Einreichung: 2024-03-06
-
NK STREAMLINE TRANSPORT LTD Firmenbeschreibung
- NK STREAMLINE TRANSPORT LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08436633. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.03.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "49320" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 16 Didcot Road erreicht werden.
Jetzt sichern NK STREAMLINE TRANSPORT LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nk Streamline Transport Ltd - 16 Didcot Road, Poole, Dorset, BH17 0GD, Grossbritannien
- 2013-03-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NK STREAMLINE TRANSPORT LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-04-30) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2024-05-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2024-03-18) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-04-23) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2024-04-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-05-23) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2023-05-23) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-05-24) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2023-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-11-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-04-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-12-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-16) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-03-25) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-01-25) - MR01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-09-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-11-25) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-20) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-14) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-16) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-16) - CH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-14) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-14) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-24) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name (2015-08-11) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-30) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-24) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-05) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-09) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-29) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-04-04) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-03-08) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-10-03) - MR01