-
HOLLY LANE CAPITAL LIMITED - 26 Holly Lane West, Banstead, Surrey, SM7 2BB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08455464
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 26 Holly Lane West
- Banstead
- Surrey
- SM7 2BB 26 Holly Lane West, Banstead, Surrey, SM7 2BB UK
Management
- Geschäftsführung
- SAVAGE, Graeme Peter
- SAVAGE, Jonathan Peter
- SAVAGE, Sharon Elizabeth
- Prokuristen
- SAVAGE, Sharon Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.03.2013
- Alter der Firma 2013-03-21 11 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Graeme Peter Savage
- Mrs Sharon Elizabeth Savage
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-04
- Letzte Einreichung: 2023-03-21
-
HOLLY LANE CAPITAL LIMITED Firmenbeschreibung
- HOLLY LANE CAPITAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08455464. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.03.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 26 Holly Lane West erreicht werden.
Jetzt sichern HOLLY LANE CAPITAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Holly Lane Capital Limited - 26 Holly Lane West, Banstead, Surrey, SM7 2BB, Grossbritannien
- 2013-03-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HOLLY LANE CAPITAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-29) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-26) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-31) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-31) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-17) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-21) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-04-15) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-22) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-05-02) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-01-30) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-01-09) - SH03
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-07) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-27) - TM01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2016-03-07) - AD03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-01) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-17) - AR01
-
change-sail-address-company-with-new-address (2015-04-17) - AD02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-11) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-03-06) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-14) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-05-11) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-09-26) - CH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-06-18) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-07) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-06-04) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-05-04) - AP03
-
incorporation-company (2013-03-21) - NEWINC