-
CREDU CHARITY LTD - MENZIES LLP, 5th Floor Hodge House 114-116 St. Mary Street, Cardiff, CF10 1DY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08612175
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- MENZIES LLP
- 5th Floor Hodge House 114-116 St. Mary Street
- Cardiff
- CF10 1DY MENZIES LLP, 5th Floor Hodge House 114-116 St. Mary Street, Cardiff, CF10 1DY UK
Management
- Geschäftsführung
- CLARKE, Michael Charles
- DARE-EDWARDS, Kim Christopher
- PARRY, Rhydian Owen Brynmor
- PEARSALL, Mark David
- Prokuristen
- CLARKE, Norah
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-limited-guarant-nsc
- Gründungsdatum
- 16.07.2013
- Alter der Firma 2013-07-16 11 Jahre
- SIC/NACE
- 93290
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Ehemalige Namen
- PORTHCAWL HARBOURSIDE CIC
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-30
- Letzte Einreichung: 2020-07-16
-
CREDU CHARITY LTD Firmenbeschreibung
- CREDU CHARITY LTD ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc registrierte Firma mit der Register-Nr. 08612175. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.07.2013 registriert. CREDU CHARITY LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PORTHCAWL HARBOURSIDE CIC ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93290" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.07.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Menzies Llp erreicht werden.
Jetzt sichern CREDU CHARITY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Credu Charity Ltd - MENZIES LLP, 5th Floor Hodge House 114-116 St. Mary Street, Cardiff, CF10 1DY, Grossbritannien
- 2013-07-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CREDU CHARITY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-disclaimer-notice (2023-01-13) - NDISC
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-01-23) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-07-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-01-19) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-24) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-24) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-11-26) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-12-07) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-12-07) - 600
-
resolution (2020-12-07) - RESOLUTIONS
-
liquidation-disclaimer-notice (2020-12-14) - NDISC
-
liquidation-disclaimer-notice (2020-12-30) - NDISC
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
statement-of-companys-objects (2018-01-24) - CC04
-
change-of-name-request-comments (2018-01-16) - NM06
-
change-of-name-notice (2018-01-16) - CONNOT
-
change-of-name-community-interest-company (2018-01-16) - CICCON
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-03) - TM01
-
resolution (2018-01-16) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-18) - AA
-
resolution (2018-01-29) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-07-26) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-07-26) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-26) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-26) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-02-23) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-28) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-28) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-09-16) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-04-23) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-04-23) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2015-09-16) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2014-08-07) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-07) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-25) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-12) - AP01
-
incorporation-community-interest-company (2013-07-16) - CICINC