-
POLYMER INDUSTRIES LIMITED - Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08721277
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Office D Beresford House
- Town Quay
- Southampton
- SO14 2AQ Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ UK
Management
- Geschäftsführung
- COOMBS, Graeme Derek Thomas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.10.2013
- Alter der Firma 2013-10-07 10 Jahre
- SIC/NACE
- 22290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Jason Arthur Goozee
- Mr John Michael Gibbins
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-10-21
- Letzte Einreichung: 2018-10-07
-
POLYMER INDUSTRIES LIMITED Firmenbeschreibung
- POLYMER INDUSTRIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08721277. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.10.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "22290" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Office D Beresford House erreicht werden.
Jetzt sichern POLYMER INDUSTRIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Polymer Industries Limited - Office D Beresford House, Town Quay, Southampton, SO14 2AQ, Grossbritannien
- 2013-10-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu POLYMER INDUSTRIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-09-07) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-12-15) - LIQ14
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-02-10) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-10-19) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-10-18) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-23) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-09-03) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-09-03) - 600
-
resolution (2019-09-03) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-19) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-13) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-11) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-01) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-05-30) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-23) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-03) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-11) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-08) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-10) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-10) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-07-03) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-27) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-13) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-16) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-06-12) - AA01
-
capital-allotment-shares (2014-03-05) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2014-01-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-10-07) - NEWINC