-
PLASTIC RECYCLING LIMITED - 14-16 Derby Road, Bootle, Liverpool, L20 8EE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08725248
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 14-16 Derby Road
- Bootle
- Liverpool
- L20 8EE 14-16 Derby Road, Bootle, Liverpool, L20 8EE UK
Management
- Geschäftsführung
- CARROLL, Simon John
- CARTMELL, David Wayne, Dr
- KEIGHLEY, Richard Nicholas
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.10.2013
- Alter der Firma 2013-10-09 10 Jahre
- SIC/NACE
- 22210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon John Carroll
- -
- Merseyside Loan And Equity Fund Llp
Landes-Besonderheiten
- Firmenname (in Englisch)
- Plastic Recycling Limited
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- BRABCO 1326 LIMITED
- UID/USt-ID-Nummer
- GB192707000
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-30
- Letzte Einreichung: 2023-08-16
-
PLASTIC RECYCLING LIMITED Firmenbeschreibung
- PLASTIC RECYCLING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08725248. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.10.2013 registriert. PLASTIC RECYCLING LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BRABCO 1326 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "22210" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 14-16 Derby Road erreicht werden.
Jetzt sichern PLASTIC RECYCLING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Plastic Recycling Limited - 14-16 Derby Road, Bootle, Liverpool, L20 8EE, Grossbritannien
- 2013-10-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PLASTIC RECYCLING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-08-17) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-group (2023-08-04) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-08-22) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2022-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-07-02) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-07-14) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-07-11) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-01-02) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-26) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-06) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-06) - PSC04
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-02-09) - SH03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-10) - AP01
-
resolution (2018-03-21) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2018-03-21) - MA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-12-18) - AA
-
capital-cancellation-shares (2018-02-09) - SH06
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-01-05) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-17) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-17) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-12-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-07-14) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-02-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-17) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-08) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-09) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-04-14) - AD01
-
capital-allotment-shares (2014-04-14) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-14) - AP01
-
change-of-name-notice (2014-04-23) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2014-04-23) - CERTNM
-
resolution (2014-04-24) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-02) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-11) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-06) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-04-14) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-10-09) - NEWINC