-
PORTWAY OFFICE SUPPORT SERVICES LIMITED - Recovery House Hainault Business Park, 15-17 Roebuck Road, Ilford, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08786182
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Recovery House Hainault Business Park
- 15-17 Roebuck Road
- Ilford
- Essex
- IG6 3TU Recovery House Hainault Business Park, 15-17 Roebuck Road, Ilford, Essex, IG6 3TU UK
Management
- Geschäftsführung
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.11.2013
- Alter der Firma 2013-11-22 10 Jahre
- SIC/NACE
- 82110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-04-30
- Letzte Einreichung: 2022-07-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-06
- Letzte Einreichung: 2022-11-22
-
PORTWAY OFFICE SUPPORT SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- PORTWAY OFFICE SUPPORT SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08786182. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.11.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82110" registriert. Die Firma kann schriftlich über Recovery House Hainault Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern PORTWAY OFFICE SUPPORT SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Portway Office Support Services Limited - Recovery House Hainault Business Park, 15-17 Roebuck Road, Ilford, Essex, Grossbritannien
- 2013-11-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PORTWAY OFFICE SUPPORT SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2023-12-30) - LIQ02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-31) - AA
-
resolution (2023-12-30) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2023-12-30) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-12-30) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-08-31) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-08-24) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-08-24) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-13) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-12-28) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-12-28) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-06-13) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-13) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-11-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-01) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-31) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-07-05) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-07-04) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-28) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-03-24) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-08-10) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-11-22) - NEWINC