-
MANIK VENTURES LIMITED - Avon View Offices 90 High Street, Bidford-On-Avon, Alcester, B50 4AF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08812605
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Avon View Offices 90 High Street
- Bidford-On-Avon
- Alcester
- B50 4AF
- England Avon View Offices 90 High Street, Bidford-On-Avon, Alcester, B50 4AF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- SPENCER, Nicholas Clark
- Prokuristen
- SPENCER, Nicholas Clark
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.12.2013
- Alter der Firma 2013-12-12 10 Jahre
- SIC/NACE
- 71129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Heru Technologies Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- MANIKS VENTURES LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-12-31
- Letzte Einreichung: 2024-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-01-01
- Letzte Einreichung: 2023-12-18
-
MANIK VENTURES LIMITED Firmenbeschreibung
- MANIK VENTURES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08812605. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.12.2013 registriert. MANIK VENTURES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MANIKS VENTURES LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71129" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Avon View Offices 90 High Street erreicht werden.
Jetzt sichern MANIK VENTURES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Manik Ventures Limited - Avon View Offices 90 High Street, Bidford-On-Avon, Alcester, B50 4AF, Grossbritannien
- 2013-12-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MANIK VENTURES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-05-28) - AA
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2024-08-06) - CH03
keyboard_arrow_right 2023
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-12-18) - PSC02
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2023-11-13) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-11-10) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-30) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-07-19) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-02-15) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-12-18) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2023-12-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-02-18) - CS01
-
resolution (2022-10-10) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2022-10-10) - SH01
keyboard_arrow_right 2021
-
resolution (2021-04-28) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-11) - CS01
-
capital-alter-shares-subdivision (2021-04-28) - SH02
-
capital-allotment-shares (2021-08-08) - SH01
-
resolution (2021-08-10) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-08-10) - MA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-10) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-11) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-13) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-13) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-29) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-29) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-06) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-09) - AR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-30) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-30) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-12-30) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name (2014-01-17) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
certificate-change-of-name-company (2013-12-17) - CERTNM
-
incorporation-company (2013-12-12) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-12-17) - AA01