-
ANTI COUNTERFEITING TECHNOLOGY COMPANY LTD - 154 Park Hill Road, Harborne, Birmingham, B17 9HD, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08839189
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 154 Park Hill Road
- Harborne
- Birmingham
- B17 9HD
- England 154 Park Hill Road, Harborne, Birmingham, B17 9HD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GOODWIN, Scott Thomas
- LE QUELENEC, Mike
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.01.2014
- Gelöscht am:
- 2021-04-27
- SIC/NACE
- 32990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Michael Vincent Le Quelenec
- -
- Mr Scott Thomas Goodwin
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-29
- Letzte Einreichung: 2019-04-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-01-22
- Letzte Einreichung: 2021-01-08
-
ANTI COUNTERFEITING TECHNOLOGY COMPANY LTD Firmenbeschreibung
- ANTI COUNTERFEITING TECHNOLOGY COMPANY LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08839189. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 09.01.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "32990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 154 Park Hill Road erreicht werden.
Jetzt sichern ANTI COUNTERFEITING TECHNOLOGY COMPANY LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Anti Counterfeiting Technology Company Ltd - 154 Park Hill Road, Harborne, Birmingham, B17 9HD, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ANTI COUNTERFEITING TECHNOLOGY COMPANY LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-04-27) - GAZ2(A)
-
gazette-notice-voluntary (2021-02-09) - GAZ1(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-10) - CS01
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-02-02) - DS01
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-17) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-17) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-01-31) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-24) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-22) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-19) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-01-17) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-19) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-20) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares-treasury-capital-date (2017-02-13) - SH03
-
capital-allotment-shares (2017-01-23) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-20) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-04-08) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-08) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-25) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-05) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-08) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-05-12) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-17) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-03-19) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-03-04) - AD01
-
capital-allotment-shares (2015-03-03) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-02-26) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-12) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-06) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-14) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-13) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-01-09) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-16) - AP01