-
HOTSPUR DRILLING LIMITED - Syon House, London Road, Brentford, TW8 8JF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08909181
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Syon House
- London Road
- Brentford
- TW8 8JF
- England Syon House, London Road, Brentford, TW8 8JF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- PERCY, George Dominic, The Honourable
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.02.2014
- Alter der Firma 2014-02-24 10 Jahre
- SIC/NACE
- 09100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Earl George Dominic Percy
- The Honourable George Dominic Percy
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-10
- Letzte Einreichung: 2021-02-24
-
HOTSPUR DRILLING LIMITED Firmenbeschreibung
- HOTSPUR DRILLING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08909181. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.02.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "09100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Syon House erreicht werden.
Jetzt sichern HOTSPUR DRILLING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hotspur Drilling Limited - Syon House, London Road, Brentford, TW8 8JF, Grossbritannien
- 2014-02-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HOTSPUR DRILLING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-02-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-12-03) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-12-03) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-07) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-24) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-10-03) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-03) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-03) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-01) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-02) - CH01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-08-01) - AP03
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-08-01) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-01) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-11-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-11-25) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-08-13) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-04) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-12) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-30) - MR01
-
capital-allotment-shares (2014-07-22) - SH01
-
resolution (2014-07-22) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-06-11) - SH01
-
incorporation-company (2014-02-24) - NEWINC
-
resolution (2014-06-11) - RESOLUTIONS