-
BERKELEY LAW NOMINEES LIMITED - Riverside East, 2 Millsands, Sheffield, South Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09004204
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Riverside East
- 2 Millsands
- Sheffield
- South Yorkshire
- S3 8DT Riverside East, 2 Millsands, Sheffield, South Yorkshire, S3 8DT UK
Management
- Geschäftsführung
- MR GEOFFREY MARTIN PICKERILL
- RUFFEL, Alexandra Marguerite
- IMCO DIRECTOR LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.04.2014
- Alter der Firma 2014-04-22 10 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Berkeley Law Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-31
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-05-06
- Letzte Einreichung: 2024-04-22
-
BERKELEY LAW NOMINEES LIMITED Firmenbeschreibung
- BERKELEY LAW NOMINEES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09004204. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.04.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Riverside East erreicht werden.
Jetzt sichern BERKELEY LAW NOMINEES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Berkeley Law Nominees Limited - Riverside East, 2 Millsands, Sheffield, South Yorkshire, Grossbritannien
- 2014-04-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BERKELEY LAW NOMINEES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-05-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2024-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
appoint-corporate-director-company-with-name-date (2023-10-20) - AP02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-08-23) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-01-19) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-10-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-01-21) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-01-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-12) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-01-17) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-26) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-27) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-11-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-12-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-19) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-07-03) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-17) - AP01
-
resolution (2014-11-17) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-11-17) - AD01
-
incorporation-company (2014-04-22) - NEWINC