-
BUCKMORE PARK KARTING LIMITED - Buckmore Park Kart Circuit, Maidstone Road, Chatham, ME5 9QG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09420699
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Buckmore Park Kart Circuit
- Maidstone Road
- Chatham
- ME5 9QG
- England Buckmore Park Kart Circuit, Maidstone Road, Chatham, ME5 9QG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- LING, Philip David
- MARTELL, Richard Lewis
- MARTELL-SURTEES, Leonora Dorothy
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.02.2015
- Alter der Firma 2015-02-04 9 Jahre
- SIC/NACE
- 93199
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- -
- Buckmore Park Holdings Limited
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SURTEES KARTING AND TRAINING LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-12-06
- Letzte Einreichung: 2022-11-22
-
BUCKMORE PARK KARTING LIMITED Firmenbeschreibung
- BUCKMORE PARK KARTING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09420699. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.02.2015 registriert. BUCKMORE PARK KARTING LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SURTEES KARTING AND TRAINING LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93199" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Buckmore Park Kart Circuit erreicht werden.
Jetzt sichern BUCKMORE PARK KARTING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Buckmore Park Karting Limited - Buckmore Park Kart Circuit, Maidstone Road, Chatham, ME5 9QG, Grossbritannien
- 2015-02-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BUCKMORE PARK KARTING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-10-27) - CH01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-24) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-11-22) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-17) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-11-23) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-08-31) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-30) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-11-06) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-03) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-03) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-03) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2019-10-03) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-07) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-11-12) - MR04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-11-22) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-06) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-02) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-02-23) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-02-14) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-12) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-12-08) - TM02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-08) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-08) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-22) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-12-08) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-19) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-01) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-25) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-22) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-08) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-14) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-08) - TM01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-03-04) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-28) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2015-04-23) - CERTNM
-
incorporation-company (2015-02-04) - NEWINC