-
ZERO CARBON SOLUTIONS LTD - C/O Frp Advisory Llp, 4 Beaconsfield Road, St Albans, Herfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09792571
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Frp Advisory Llp
- 4 Beaconsfield Road
- St Albans
- Herfordshire
- AL1 3RD C/O Frp Advisory Llp, 4 Beaconsfield Road, St Albans, Herfordshire, AL1 3RD UK
Management
- Geschäftsführung
- EVANS, Brian James
- MOONEY, David Matthew
- ROBSON, Adam John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.09.2015
- Alter der Firma 2015-09-24 8 Jahre
- SIC/NACE
- 71129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Gary Martyn Bennett
- Mr Adam John Robson
- Mr Brian James Evans
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-06-30
- Letzte Einreichung: 2017-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-06-06
- Letzte Einreichung: 2018-05-23
-
ZERO CARBON SOLUTIONS LTD Firmenbeschreibung
- ZERO CARBON SOLUTIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09792571. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.09.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71129" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Frp Advisory Llp erreicht werden.
Jetzt sichern ZERO CARBON SOLUTIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Zero Carbon Solutions Ltd - C/O Frp Advisory Llp, 4 Beaconsfield Road, St Albans, Herfordshire, Grossbritannien
- 2015-09-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ZERO CARBON SOLUTIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-03-30) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-04-03) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-02-28) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2019-02-27) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-02-27) - 600
-
resolution (2019-02-27) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-11-27) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2018-11-21) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-06) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-07-09) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-23) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-03-13) - PSC04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-13) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-09) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-09) - PSC01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-03-13) - CH01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-26) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-19) - CS01
-
capital-allotment-shares (2016-09-15) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-15) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-01) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
incorporation-company (2015-09-24) - NEWINC