-
DREAMSTORE (UK) - 50 Bedford Street, Belfast, BT2 7FW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI046845
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 50 Bedford Street
- Belfast
- BT2 7FW 50 Bedford Street, Belfast, BT2 7FW UK
Management
- Geschäftsführung
- CAMPBELL, Melfort Andrew
- HAWKINS, Nigel Charles
- TELLWRIGHT, Mark Christopher
- WILLS, Richard Arnold
- Prokuristen
- CYPHER SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- private-limited-guarant-nsc-limited-exemption
- Gründungsdatum
- 18.06.2003
- Gelöscht am:
- 2024-03-01
- SIC/NACE
- 93290
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-06-18
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-07-30
- Letzte Einreichung: 2019-06-18
-
DREAMSTORE (UK) Firmenbeschreibung
- DREAMSTORE (UK) ist eine in Grossbritannien als private-limited-guarant-nsc-limited-exemption registrierte Firma mit der Register-Nr. NI046845. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 18.06.2003 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "93290" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30/06/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 18.06.2012.Die Firma kann schriftlich über 50 Bedford Street erreicht werden.
Jetzt sichern DREAMSTORE (UK) HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dreamstore (Uk) - 50 Bedford Street, Belfast, BT2 7FW, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DREAMSTORE (UK) aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-dissolved-liquidation (2024-03-01) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2023
-
liquidation-liquidation-statement-of-receipts-and-payments-northern-ireland-with-brought-down-date (2023-06-23) - 4.69(NI)
-
liquidation-return-of-final-meeting-members-voluntary-winding-up-northern-ireland (2023-12-01) - 4.72(NI)
-
liquidation-liquidation-statement-of-receipts-and-payments-northern-ireland-with-brought-down-date (2023-12-01) - 4.69(NI)
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-liquidation-statement-of-receipts-and-payments-northern-ireland-with-brought-down-date (2022-01-07) - 4.69(NI)
-
liquidation-liquidation-statement-of-receipts-and-payments-northern-ireland-with-brought-down-date (2022-06-21) - 4.69(NI)
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-07-02) - RESOLUTIONS
-
liquidation-appointment-of-liquidator (2020-07-02) - VL1
-
liquidation-declaration-of-solvency-northern-ireland (2020-07-02) - 4.71(NI)
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-07-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-06-28) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-06-28) - PSC08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-01-11) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2016-06-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-01-15) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-03-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2015-07-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date (2014-09-03) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-04-03) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2013-06-21) - RP04
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-09) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2013-07-31) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-07-30) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2013-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2012-07-09) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2012-03-23) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2012-07-09) - CH01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2011-06-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-07-07) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-12-13) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-no-member-list (2010-07-07) - AR01
-
change-corporate-secretary-company-with-change-date (2010-07-07) - CH04
-
accounts-with-accounts-type-full (2010-04-20) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-07-26) - 371S(NI)
-
legacy (2009-05-13) - AC(NI)
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-07-01) - 371S(NI)
-
legacy (2008-04-18) - AC(NI)
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-06-27) - 371S(NI)
-
legacy (2007-06-26) - AC(NI)
keyboard_arrow_right 2006
-
legacy (2006-06-22) - 371S(NI)
-
legacy (2006-04-02) - AC(NI)
-
legacy (2006-01-08) - 296(NI)
keyboard_arrow_right 2005
-
legacy (2005-07-06) - 371S(NI)
-
legacy (2005-04-21) - AC(NI)
keyboard_arrow_right 2004
-
legacy (2004-07-08) - 371S(NI)
-
resolution (2004-06-26) - RESOLUTIONS
-
legacy (2004-06-26) - UDM+A(NI)
keyboard_arrow_right 2003
-
legacy (2003-06-18) - G23(NI)
-
legacy (2003-06-18) - MEM(NI)
-
legacy (2003-06-18) - 40-5A(NI)
-
legacy (2003-06-18) - G21(NI)
-
legacy (2003-06-18) - ARTS(NI)