-
TOTAL RELOCATION SOLUTIONS LIMITED - Arnott House, 12-16 Bridge Street, Belfast, BT1 1LU, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI605562
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Arnott House
- 12-16 Bridge Street
- Belfast
- BT1 1LU
- Northern Ireland Arnott House, 12-16 Bridge Street, Belfast, BT1 1LU, Northern Ireland UK
Management
- Geschäftsführung
- ROSING, Robert Joseph
- BLACK, Kara M
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.12.2010
- Alter der Firma 2010-12-20 13 Jahre
- SIC/NACE
- 52103
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-20
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-24
- Letzte Einreichung: 2023-11-10
-
TOTAL RELOCATION SOLUTIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- TOTAL RELOCATION SOLUTIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI605562. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "52103" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 20.12.2012.Die Firma kann schriftlich über Arnott House erreicht werden.
Jetzt sichern TOTAL RELOCATION SOLUTIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Total Relocation Solutions Limited - Arnott House, 12-16 Bridge Street, Belfast, BT1 1LU, Grossbritannien
- 2010-12-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TOTAL RELOCATION SOLUTIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-11-10) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-04-14) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-03-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-08-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-05) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-06-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-06-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-23) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-11-07) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-04) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2018-05-14) - PSC08
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-23) - CS01
-
resolution (2017-03-15) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-11-01) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-06) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-12-06) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-06) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-11-22) - MR04
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-26) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-08-01) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-21) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-12-21) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-05) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-17) - AR01
-
resolution (2014-03-26) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-03-26) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-08-14) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-08-22) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-11-23) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
appoint-person-director-company-with-name (2011-10-05) - AP01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-20) - NEWINC